GASODUCTO DE EXTREMADURA SA

Sin información / Ranking ventas

Detalle del BORME de GASODUCTO DE EXTREMADURA SA con CIF A81100687

en el Registro Mercantil de MADRID.
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000277301 - Fecha Acto: 08/06/2021
    Ceses/Dimisiones. Secretario: PIQUERAS BAUTISTA RAFAEL
    VsecrNoConsj: PEREZ MIRANDA CASTILLO MARIA TERESA
    Consejero: NIETO PRIETO ROSA
    Consejero: ADAN RODRIGUEZ MARIA PAZ
    Presidente: RODRIGUEZ SUAREZ CLAUDIO PEDRO
    Consejero: RODRIGUEZ SUAREZ CLAUDIO PEDRO
    Consejero: GOMES PEREIRA HUGO FILIPE
    Consejero: HERRERA CASTRO FERNANDO
    Nombramientos. Liquidador: PIQUERAS BAUTISTA RAFAEL
    Disolución. Voluntaria
    Extinción.
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 28863 , F186, S 8, H M 157818, I/A 105 ( 1.06.21)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000196363 - Fecha Acto: 29/04/2021
    Reducción de capital. Importe reducción: 4.508.500,00 Euros
    Resultante Suscrito: 63.500,00 Euros
    Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Capital social.- Nueva redacción de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 28863 ,F 185, S 8, H M 157818, I/A 104 (22.04.21)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000400453 - Fecha Acto: 18/11/2020
    Revocaciones. Apoderado: ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES
    Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ GONZALEZADORACION
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 28863 , F 184, S 8, H M 157818, I/A 103 (11.11.20)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000381609 - Fecha Acto: 06/11/2020
    Ceses/Dimisiones. Consejero: SIMOES DIAS DOS SANTOS SEVERINO ANA ISABEL
    Consejero: CARMONA DE OLIVEIRA RICARDOPEDRO
    Nombramientos. Consejero: GOMES PEREIRA HUGO FILIPE
    Consejero: HERRERA CASTRO FERNANDO
    Reelecciones. Presidente: RODRIGUEZ SUAREZ CLAUDIO PEDRO
    Consejero: RODRIGUEZ SUAREZ CLAUDIO PEDRO
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T28863 , F 184, S 8, H M 157818, I/A 102 (29.10.20)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000186145 - Fecha Acto: 18/06/2020
    Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESCURIN GALLARDO VICTOR
    Apoderado: ESCURIN GALLARDO VICTOR
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T28863 , F 184, S 8, H M 157818, I/A 101 (11.06.20)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000184807 - Fecha Acto: 17/06/2020
    Reducción de capital. Importe reducción: 3.000.750,00 Euros
    Resultante Suscrito: 4.572.000,00 Euros
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 28863, F 178, S 8, H M 157818, I/A 100 (10.06.20)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000437687 - Fecha Acto: 22/10/2019
    Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 28863 , F 178, S 8, H M 157818, I/A 99 (15.10.19)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000331872 - Fecha Acto: 30/07/2019
    Reelecciones. Consejero: CARMONA DE OLIVEIRA RICARDO PEDRO
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 28863 , F 178, S 8, H M 157818, I/A98 (23.07.19)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000328719 - Fecha Acto: 29/07/2019
    Nombramientos. Apoderado: CRISTOBAL BEUNZA IÑIGO
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 28863 , F 177, S 8, H M 157818, I/A 97 (19.07.19)
  • GASODUCTO DE EXTREMADURA SA -   Nº Acto: 000178111 - Fecha Acto: 23/04/2019
    Reducción de capital. Importe reducción: 3.000.000,00 Euros
    Resultante Suscrito: 7.572.750,00 Euros
    Modificacionesestatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 5º Y 6º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE LAREDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
    Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 28863 , F 176, S 8, H M 157818, I/A 96 (12.04.19)

Ver más actos del borme

  • Cerrar
  • PREMIUM
  • Informes Comerciales
  • Ranking empresas
  • Servicios
    • Empresas nuevas
    • Registro Mercantil
    • Calculadora IBAN
  • Licitaciones
  • Noticias
  • Acceso